Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés

Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2009-07-18

Active Signs Inc.

001441693

2009-07-18

Aerodynamix, Aviation Services Inc.

001077000

2009-07-18

Affordable Cremation Inc.

001550716

2009-07-18

Airtv Development Limited/Developpement  Airtv Limitee

001448822

2009-07-18

Alpha Centric Solutions Inc.

001564219

2009-07-18

Ann Powell Ltd.

001244983

2009-07-18

Arc Rein Corporation

002041912

2009-07-18

Argana Inc.

001625263

2009-07-18

Asling-Mactaggart Construction Limited

000755169

2009-07-18

Axel Enterprises Ltd.

002043622

2009-07-18

Calming Kneads Inc.

002003131

2009-07-18

Canadian General Exporters Inc.

001437990

2009-07-18

Canper Resources Inc.

000071508

2009-07-18

Capital House Corporation

001504083

2009-07-18

Cash For Your Home Inc.

002012594

2009-07-18

Choufani Enterprises Ltd.

001608244

2009-07-18

Covex Systems Inc.

001449583

2009-07-18

Crawford Capital Corporation

000796814

2009-07-18

Databorough North America Inc.

001081248

2009-07-18

Eastcoast Management Inc.

000562382

2009-07-18

Entretel Incorporated

000810775

2009-07-18

Eye3 Inc.

001610423

2009-07-18

Farnaj Foods Inc.

002038335

2009-07-18

Ferraro Investments Inc.

002015098

2009-07-18

Fsm Logistic & Transportation Inc.

002059609

2009-07-18

G. Sakorafas Ltd.

000360137

2009-07-18

Gapes Holdings Plc Inc.

001505852

2009-07-18

Glenny’s Butchery & Deli Inc.

002091871

2009-07-18

Globex Motors Inc.

000897239

2009-07-18

Glorayne Excavating Inc.

000584103

2009-07-18

Gulle Dasht Enterprise Inc.

001599885

2009-07-18

H.I.S. Fixtures & Design Inc.

001586155

2009-07-18

Hidden Island Resort Ltd.

000618743

2009-07-18

India Paan Inc.

001511473

2009-07-18

Kelmat Graphics Inc.

001402585

2009-07-18

Kip Holdings Inc.

001585321

2009-07-18

Leclerc Delimbing Inc.

000661344

2009-07-18

Media Nomadz Inc.

001652374

2009-07-18

Mywill Trading Inc.

002052709

2009-07-18

Nika Foodservice Solutions Ltd.

001195778

2009-07-18

Notre Dame Restaurant Ltd.

001498346

2009-07-18

Ocean Fish And Seafood Market Inc.

001503792

2009-07-18

Pasta People Inc.

001049120

2009-07-18

Patiala Logistics Inc.

002078344

2009-07-18

Peter D’S Ltd.

000671761

2009-07-18

Sales Tactics Inc.

001411528

2009-07-18

Saxxonatm Inc.

001503646

2009-07-18

Skydome Truck Centre Inc.

002021839

2009-07-18

Smurf’s Tire Incorporated

001400781

2009-07-18

Speke Holdings Limited

000506753

2009-07-18

Stefilea Holdings Inc.

001180097

2009-07-18

Taromi Investment Corp.

002021178

2009-07-18

Tech-Pro Personnel Ltd.

001551172

2009-07-18

Tekemed Inc.

000981758

2009-07-18

The Greater Niagara Trading Company Ltd.

000954829

2009-07-18

The Plusar Equipment Corporation

000874755

2009-07-18

The Silicon Network Inc.

001053363

2009-07-18

Timemetrics Inc.

001476503

2009-07-18

Top Seal Roofing Inc.

001556387

2009-07-18

Turbo Realty Ltd.

000336273

2009-07-18

Var Business Systems Inc.

001206177

2009-07-18

Webor Boilers Limited

000970849

2009-07-18

Winbig Sports Inc.

001567264

2009-07-18

Wolfe Island Business Center Inc.

001518092

2009-07-18

Wynn’s Furniture And Appliances Inc.

002046257

2009-07-18

Zeal Consulting & Systems Inc.

001202916

2009-07-18

Zeez Sports Bar Inc.

001206743

2009-07-18

Zen Records Limited

001282569

2009-07-18

1027707 Ontario Limited

001027707

2009-07-18

1033298 Ontario Inc.

001033298

2009-07-18

1047028 Ontario Ltd.

001047028

2009-07-18

1084672 Ontario Inc.

001084672

2009-07-18

1158444 Ontario Limited

001158444

2009-07-18

1159718 Ontario Inc.

001159718

2009-07-18

1160143 Ontario Limited

001160143

2009-07-18

1164093 Ontario Limited

001164093

2009-07-18

1177713 Ontario Limited

001177713

2009-07-18

1191313 Ontario Ltd.

001191313

2009-07-18

1203401 Ontario Inc.

001203401

2009-07-18

1243686 Ontario Limited

001243686

2009-07-18

1244568 Ontario Ltd.

001244568

2009-07-18

1248969 Ontario Ltd.

001248969

2009-07-18

1266834 Ontario Limited

001266834

2009-07-18

1342615 Ontario Inc.

001342615

2009-07-18

1375733 Ontario Inc.

001375733

2009-07-18

1389065 Ontario Inc.

001389065

2009-07-18

1389794 Ontario Inc.

001389794

2009-07-18

1405159 Ontario Limited

001405159

2009-07-18

1429524 Ontario Inc.

001429524

2009-07-18

1440695 Ontario Inc.

001440695

2009-07-18

1445558 Ontario Inc.

001445558

2009-07-18

1450630 Ontario Inc.

001450630

2009-07-18

1462615 Ontario Limited

001462615

2009-07-18

1470535 Ontario Inc.

001470535

2009-07-18

1502499 Ontario Inc.

001502499

2009-07-18

1551552 Ontario Ltd.

001551552

2009-07-18

1558399 Ontario Limited

001558399

2009-07-18

1558927 Ontario Ltd.

001558927

2009-07-18

1566094 Ontario Limited

001566094

2009-07-18

1586293 Ontario Ltd.

001586293

2009-07-18

1590636 Ontario Inc.

001590636

2009-07-18

1601791 Ontario Ltd.

001601791

2009-07-18

1610240 Ontario Limited

001610240

2009-07-18

1613251 Ontario Inc.

001613251

2009-07-18

1613717 Ontario Limited

001613717

2009-07-18

1616641 Ontario Limited

001616641

2009-07-18

1629724 Ontario Inc.

001629724

2009-07-18

1630260 Ontario Inc.

001630260

2009-07-18

2039440 Ontario Inc.

002039440

2009-07-18

2040340 Ontario Ltd.

002040340

2009-07-18

2046499 Ontario Inc.

002046499

2009-07-18

2069938 Ontario Ltd.

002069938

2009-07-18

2073010 Ontario Limited

002073010

2009-07-18

2074297 Ontario Inc.

002074297

2009-07-18

2090427 Ontario Ltd.

002090427

2009-07-18

391308 Ontario Inc.

000391308

2009-07-18

428609 Ontario Limited

000428609

2009-07-18

819853 Ontario Limited

000819853

2009-07-18

824919 Ontario Limited

000824919

2009-07-18

891749 Ontario Inc.

000891749


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(142-G388)

Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2009-06-22

Abenan Inc.

001571343

2009-06-22

Absolute Quality Services Inc.

001189541

2009-06-22

Advance Home Decors And Wholesale Inc.

001654140

2009-06-22

Aladdin & Jasmine Restaurant & Cafe Inc.

001510757

2009-06-22

Aries Computer Systems Inc.

001267718

2009-06-22

Autoworks Toronto Limited

002038138

2009-06-22

Boland Carpentry Inc.

001528945

2009-06-22

C & A Gift Shoppes Ltd.

001320135

2009-06-22

Canadian International Education Service  Center Ltd.

001653404

2009-06-22

Champlain Inc.

001557892

2009-06-22

Cheelina Enterprises Ltd.

000974993

2009-06-22

Cia Public Auto Auction & Sales Inc.

002016228

2009-06-22

Cineasst Inc.

001102603

2009-06-22

City Medical Assessment Centre Inc.

001489037

2009-06-22

Cunkoccino Inc.

001543233

2009-06-22

Dave Nickerson Excavating Ltd.

000431348

2009-06-22

Davel Productions Inc.

000903863

2009-06-22

De-Home Improvements & Renovations Inc.

001487603

2009-06-22

Diamondoptics Inc.

002010760

2009-06-22

Eastgate Consultants Inc.

001314117

2009-06-22

European (I) Limited

000777156

2009-06-22

F.D.S. Ontario Ltd.

001443759

2009-06-22

G & M Custom Contracting Ltd.

001043154

2009-06-22

G. L. R. Gaudio Restaurant Ltd.

000741109

2009-06-22

Global Cryogenics Inc.

001573221

2009-06-22

Harmonic Happenings Inc.

001609045

2009-06-22

High Park Holdings Inc.

000823384

2009-06-22

Huron Shores Artisans And Antiques Mall Inc.

001273900

2009-06-22

Hydranet Solutions Inc.

001044055

2009-06-22

Iline Media Inc.

000658450

2009-06-22

Itcm Consulting Inc.

001323961

2009-06-22

J&J Engine Inc.

001474255

2009-06-22

Jozef Design Studio Inc.

000938662

2009-06-22

Kraczynski Tennis Inc.

001301046

2009-06-22

Lamway Systems Inc.

000675285

2009-06-22

Le Cercle Des Six Ltd.

000363279

2009-06-22

Lengenco Inc.

000700491

2009-06-22

Lewis & Clark Shipping Limited

001014663

2009-06-22

Lewis Bakeries Inc.

001142052

2009-06-22

Liberty Road Lines Ltd.

001461337

2009-06-22

Like A Fox Inc.

001518651

2009-06-22

Live Feed Inc.

001653419

2009-06-22

M & S Car Care Inc.

001033773

2009-06-22

Melanson Generator Services Inc.

000951511

2009-06-22

Microwonders Inc.

001061931

2009-06-22

Moore-Con Construction Inc.

001299641

2009-06-22

New Generation Sprinkler Design Inc.

001527590

2009-06-22

New York Furniture Co. Limited

000139008

2009-06-22

Otris Inc.

001567262

2009-06-22

Paula & Mina Inc.

001250954

2009-06-22

Pcdream Ltd.

002056430

2009-06-22

Polo Mega-Media Productions Inc.

001072704

2009-06-22

Powermerchant Inc.

001518650

2009-06-22

Ram Petroleums Limited

000091740

2009-06-22

Rational Approach Inc.

001125276

2009-06-22

Rdi Rock Drillers Inc.

001382864

2009-06-22

Screen Engine Inc.

001379250

2009-06-22

Seal Management Consulting Ltd.

001400794

2009-06-22

Securkey Systems Inc.

000684649

2009-06-22

Sha Products Ltd.

001505389

2009-06-22

Softsmith Systems Inc.

000799166

2009-06-22

Strictly Culture Inc.

001653564

2009-06-22

Sunwin Travels And Tours Inc.

001155677

2009-06-22

Synerstrat Corporation

000952073

2009-06-22

The 21St Century Traveler Inc.

001408885

2009-06-22

Travul Consulting Inc.

001376010

2009-06-22

Unified Motors Inc.

001007183

2009-06-22

United Cement Finish Ltd.

000996609

2009-06-22

Virk Auto Services Inc.

001574622

2009-06-22

Winsor Massage & Shiatsu Clinic Ltd.

000949189

2009-06-22

1015323 Ontario Inc.

001015323

2009-06-22

1032209 Ontario Limited

001032209

2009-06-22

1052006 Ontario Inc.

001052006

2009-06-22

1072565 Ontario Limited

001072565

2009-06-22

1080383 Ontario Ltd.

001080383

2009-06-22

1082221 Ontario Ltd.

001082221

2009-06-22

1118477 Ontario Limited

001118477

2009-06-22

1133386 Ontario Inc.

001133386

2009-06-22

1136356 Ontario Ltd.

001136356

2009-06-22

1137738 Ontario Inc.

001137738

2009-06-22

1164316 Ontario Inc.

001164316

2009-06-22

1227969 Ontario Ltd.

001227969

2009-06-22

1229118 Ontario Inc.

001229118

2009-06-22

1229372 Ontario Inc.

001229372

2009-06-22

1235371 Ontario Inc.

001235371

2009-06-22

1306435 Ontario Inc.

001306435

2009-06-22

1331894 Ontario Ltd.

001331894

2009-06-22

1349479 Ontario Inc.

001349479

2009-06-22

1380531 Ontario Limited

001380531

2009-06-22

1442506 Ontario Limited

001442506

2009-06-22

1443657 Ontario Inc.

001443657

2009-06-22

1447533 Ontario Ltd.

001447533

2009-06-22

1454163 Ontario Limited

001454163

2009-06-22

1466143 Ontario Inc.

001466143

2009-06-22

1479311 Ontario Inc.

001479311

2009-06-22

1486206 Ontario Inc.

001486206

2009-06-22

1505014 Ontario Limited

001505014

2009-06-22

1508158 Ontario Limited

001508158

2009-06-22

1524088 Ontario Limited

001524088

2009-06-22

1549947 Ontario Inc.

001549947

2009-06-22

1564409 Ontario Inc.

001564409

2009-06-22

1621896 Ontario Ltd.

001621896

2009-06-22

1622064 Ontario Inc.

001622064

2009-06-22

1636582 Ontario Limited

001636582

2009-06-22

2027366 Ontario Inc.

002027366

2009-06-22

2056910 Ontario Limited

002056910

2009-06-22

2058168 Ontario Inc.

002058168

2009-06-22

364116 Ontario Limited

000364116

2009-06-22

817352 Ontario Inc.

000817352

2009-06-22

839329 Ontario Limited

000839329

2009-06-22

918933 Ontario Limited

000918933

2009-06-22

930441 Ontario Limited

000930441

2009-06-22

935678 Ontario Ltd.

000935678


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(142-G389)

Certificat de dissolution

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2009-05-21

1156940 Ontario Limited

001156940

2009-05-25

Canada Wantong Immigration And Business  Consulting Ltd.

001743337

2009-06-05

Kirolos Foods Limited

002154226

2009-06-10

Accelerated Capital Investments Ltd.

001616957

2009-06-10

Anthony Marson Developments Limited

000903400

2009-06-10

Bolte Technologies Limited

001270445

2009-06-10

C.D.Z. International Inc.

001048716

2009-06-10

Close Enough Productions Inc.

001204375

2009-06-10

Forum Leasehold Audits Ltd.

002024555

2009-06-10

Greenmaster Garden Centre Inc.

001128276

2009-06-10

Hood Investment Planning Inc.

000844585

2009-06-10

Ladhian Transport Inc.

002021458

2009-06-10

Rideau Technical Systems Incorporated

001041012

2009-06-10

T.E. Walsh & Associates Inc.

001085203

2009-06-10

Tri K Group Ltd.

001651105

2009-06-10

1467189 Ontario Inc.

001467189

2009-06-10

1612033 Ontario Ltd.

001612033

2009-06-10

1641640 Ontario Inc.

001641640

2009-06-10

1720735 Ontario Limited

001720735

2009-06-10

698814 Ontario Ltd.

000698814

2009-06-11

Advancement Plus Inc.

002014704

2009-06-11

Alexandra Studio (Turofsky)  Photographers Limited

000138084

2009-06-11

Bj Kitchen Cabinets Corporation

001756661

2009-06-11

Clarke Wallace Ltd.

000626040

2009-06-11

Duff And Mcguire Computer Consulting Inc.

001078001

2009-06-11

Elite Clothing Inc.

001634706

2009-06-11

F. Moreau Farm Equipment Limited

000744603

2009-06-11

Famo Construction Limited

000828755

2009-06-11

Groomer’s Warehouse And Supply Inc.

000712663

2009-06-11

Laurentian Masonry (1996) Inc.

001141442

2009-06-11

Li’l Al’s Custom Vans Ltd.

000445737

2009-06-11

Lunch Break Restaurant Inc.

002110371

2009-06-11

Macklem Technology Services Inc.

001272918

2009-06-11

Oriental Food Distribution Centre Inc.

001607556

2009-06-11

Priority Products And Promotions Inc.

001282532

2009-06-11

Weston Wholesale & Mobile Equipment Ltd.

001506800

2009-06-11

Wyle E. Consultants Inc.

000546837

2009-06-11

1153728 Ontario Inc.

001153728

2009-06-11

1230945 Ontario Inc.

001230945

2009-06-11

1267167 Ontario Inc.

001267167

2009-06-11

1310395 Ontario Ltd.

001310395

2009-06-11

1369659 Ontario Inc.

001369659

2009-06-11

1569632 Ontario Inc.

001569632

2009-06-11

2147807 Ontario Inc.

002147807

2009-06-12

Aces Wild Inc.

002043951

2009-06-12

B. D. H. Associates Inc.

000631319

2009-06-12

Bottles By Design Inc.

001419462

2009-06-12

Carlson Enterprises Inc.

001323416

2009-06-12

Catalina Spas Canada Inc.

002006486

2009-06-12

Coural Consulting Inc.

002140051

2009-06-12

Dogbyte Systems Inc.

001294445

2009-06-12

Douglas R. Watson Management  Resources Inc.

000712549

2009-06-12

Fast Motor Freight Inc.

002094898

2009-06-12

Hue Vinh Ltd.

001553489

2009-06-12

Humanetics Inc.

000544277

2009-06-12

Jordel Acres Inc.

001374783

2009-06-12

Manitou Seguin Fish & Game Group Inc.

000837709

2009-06-12

Nulife Fibres Inc.

001473387

2009-06-12

Polypure Ltd.

001171199

2009-06-12

R.J. Railroad-Transportation Consultant Inc.

001361139

2009-06-12

Rosental Trading Company Limited

001599428

2009-06-12

Wei Long Sewing Machine Inc.

001568008

2009-06-12

1248487 Ontario Inc.

001248487

2009-06-12

1273818 Ontario Limited

001273818

2009-06-12

1309940 Ontario Inc.

001309940

2009-06-12

1381907 Ontario Ltd.

001381907

2009-06-12

1397887 Ontario Limited

001397887

2009-06-12

1576181 Ontario Inc.

001576181

2009-06-12

1622573 Ontario Inc.

001622573

2009-06-12

1674596 Ontario Inc.

001674596

2009-06-12

2137941 Ontario Inc.

002137941

2009-06-12

700521 Ontario Limited

000700521

2009-06-12

88 Real Estate Inc.

001360404

2009-06-12

970459 Ontario Inc.

000970459

2009-06-15

Inn-Teriors Plus Inc.

000601175

2009-06-16

Bourget Energym Inc.

001649357

2009-06-16

Century Ct Inc.

002110514

2009-06-16

China Commerce Trading Company Ltd.

000697413

2009-06-16

Edgehill Park Developments Inc.

001417723

2009-06-16

Golden Lion Enterprises Inc.

001040165

2009-06-16

Grand-Dix Developments Limited

000146722

2009-06-16

Joymor Sales Inc.

001154363

2009-06-16

Kiddies Catering Inc.

001632432

2009-06-16

Leman Group Inc. Consultants

001090161

2009-06-16

Manninger Bros. Construction (1978) Ltd.

000380803

2009-06-16

Maxim Painting Inc.

001707943

2009-06-16

Mcw Group Inc.

001550126

2009-06-16

Platinum Ridge Corporation

001570210

2009-06-16

Sandra Trading Inc.

001549697

2009-06-16

Seeb Import & Export Ltd.

001415002

2009-06-16

1128745 Ontario Inc.

001128745

2009-06-16

1219199 Ontario Limited

001219199

2009-06-16

1287747 Ontario Inc.

001287747

2009-06-16

1290039 Ontario Inc.

001290039

2009-06-16

1441528 Ontario Inc.

001441528

2009-06-16

1459856 Ontario Inc.

001459856

2009-06-16

1692816 Ontario Inc.

001692816

2009-06-16

2046005 Ontario Inc.

002046005

2009-06-16

2046050 Ontario Inc.

002046050

2009-06-16

2065357 Ontario Inc.

002065357

2009-06-16

2140005 Ontario Inc.

002140005

2009-06-16

310 Fairway Road Limited

002017375

2009-06-17

Circolo Caffe Inc.

002117021

2009-06-17

1184707 Ontario Inc.

001184707

2009-06-20

Arorus Consulting Services Inc.

001387742

2009-06-22

Bigdeal Inc.

001612044

2009-06-22

Bristol Circle Investments Limited

002091975

2009-06-22

Matherton Development Corporation

001219559

2009-06-22

Zarcone Foods Limited

000779424

2009-06-22

1016337 Ontario Inc.

001016337

2009-06-22

1192785 Ontario Limited

001192785

2009-06-22

1265440 Ontario Limited

001265440

2009-06-22

1354219 Ontario Inc.

001354219

2009-06-22

1698657 Ontario Ltd.

001698657

2009-06-22

590114 Ontario Inc.

000590114

2009-06-22

786713 Ontario Inc.

000786713

2009-06-22

968476 Ontario Ltd.

000968476

2009-06-23

Cook Bros. Drainage Contractors Limited

001589867

2009-06-23

Vm Management Ltd.

001117370

2009-06-24

Enovasoft Inc.

001756343

2009-06-24

Macdonald Money Management Inc.

001317762

2009-06-24

Seneca Hill Edu World Inc.

001754392

2009-06-24

Your Place Restaurant And Tavern Ltd.

000708051

2009-06-25

Buck’s Welding & Consulting Services Inc.

002016435

2009-06-25

C-K Alignment Service Inc.

000459359

2009-06-25

Elrom Services Ltd.

001368081

2009-06-25

Healthy Computers Inc.

001532560

2009-06-25

Paradis Culligan Painting & Carpentry Ltd.

001733059

2009-06-25

Peel I.T. Consultants Ltd.

001208669

2009-06-25

Rouge Valley Carpenters Inc.

000907777

2009-06-25

Tony Oliveri Painting & Decorating Ltd.

000648443

2009-06-25

Trophy Components House Ltd.

002180310

2009-06-25

1427199 Ontario Inc.

001427199

2009-06-25

1477162 Ontario Inc.

001477162

2009-06-25

1496867 Ontario Inc.

001496867

2009-06-25

2081481 Ontario Inc.

002081481

2009-06-25

737978 Ontario Ltd.

000737978

2009-06-26

B & B Flowers & Gifts Inc.

000991609

2009-06-26

Bertram Bros. Building Materials Ltd.

000534004

2009-06-26

Bertram Bros. Construction Ltd.

000534005

2009-06-26

Bs Hospitality Inc.

002073879

2009-06-26

Chemcraft Coatings Limited

001758574

2009-06-26

Dave’s Custom Carpentry (Muskoka) Ltd.

000908209

2009-06-26

Dupont Carburetor Rebuilders Ltd.

000446425

2009-06-26

E.C. I.T. Consulting Incorporated

002180286

2009-06-26

Exosity Inc.

001563444

2009-06-26

Immensity Engineering Limited

001222482

2009-06-26

K & M West Indian Canadian Groceries Inc.

002090398

2009-06-26

Kotzer Realty Ltd.

002066239

2009-06-26

Maxam Originals Corporation

000912837

2009-06-26

Nce Diversified Management (07) Corp.

002119278

2009-06-26

Power Vision Inc.

001294355

2009-06-26

Ranwat Ltd.

001008643

2009-06-26

Topway Interfurn Int’l Ltd.

001286910

2009-06-26

Vidian Trading Canada Ltd.

001333222

2009-06-26

Wiseonline Inc.

001369692

2009-06-26

1001512 Ontario Inc.

001001512

2009-06-26

1251489 Ontario Limited

001251489

2009-06-26

1293533 Ontario Limited

001293533

2009-06-26

1365705 Ontario Inc.

001365705

2009-06-26

1462152 Ontario Limited

001462152

2009-06-26

1663054 Ontario Limited

001663054

2009-06-26

1714926 Ontario Inc.

001714926

2009-06-26

2034759 Ontario Inc.

002034759

2009-06-29

Anik Management Consultants Ltd.

000894349

2009-06-29

B. Labron Occupational Therapy  Professional Corporation

001535309

2009-06-29

C. Lewis Social Work Professional  Corporation

001535400

2009-06-29

D. Beattie Speech-Language Pathology  Professional Corporation

001535308

2009-06-29

Dim Refridgeration Aircondition  Services Inc.

001709099

2009-06-29

E. Hill Registered Dietitian Professional  Corporation

001535307

2009-06-29

G. Tanner Physiotherapy Professional  Corporation

001535349

2009-06-29

Integrated Optical Systems Inc.

002167326

2009-06-29

J. Sertal Construction Inc.

000790563

2009-06-29

Norada Developments Inc.

000521941

2009-06-29

Pinedale Inn Motel Ltd.

001489532

2009-06-29

Powerwindows Inc.

001097967

2009-06-29

Procare Canada Inc.

001257412

2009-06-29

Rabb Construction Inc.

001085011

2009-06-29

Radiocorp Management Inc.

001014227

2009-06-29

T & T Auto Towing Inc.

001712347

2009-06-29

Universal Channel Canada Inc.

001591669

2009-06-29

Worldwide Adventures-Wwa India Inc.

001577397

2009-06-29

Yuchen Communications Inc.

002076751

2009-06-29

101846 Ontario Inc.

000101846

2009-06-29

1020932 Ontario Inc.

001020932

2009-06-29

1306657 Ontario Limited

001306657

2009-06-29

1486467 Ontario Inc.

001486467

2009-06-29

1614723 Ontario Inc.

001614723

2009-06-29

1760593 Ontario Ltd.

001760593

2009-06-29

2045233 Ontario Limited

002045233

2009-06-29

2065007 Ontario Inc.

002065007

2009-06-29

2065742 Ontario Inc.

002065742

2009-06-29

2082613 Ontario Inc.

002082613

2009-06-29

2115673 Ontario Inc.

002115673

2009-06-29

340909 Ontario Ltd.

000340909

2009-06-30

Art Assets Corporation

002072589

2009-06-30

Artima S.H. Inc.

000999942

2009-06-30

Comfy Cafe Inc.

001522330

2009-06-30

Cps Construction Project Solutions Inc.

001681169

2009-06-30

Etm & Peter Inc.

001430248

2009-06-30

For All Seasons Merchandising Inc.

001411563

2009-06-30

Garage On Wheels Inc.

000440941

2009-06-30

Indeera Investmets Inc.

001629206

2009-06-30

Innispen Investments Inc.

000910581

2009-06-30

Medical Market Communication Ltd.

001434514

2009-06-30

Michael D. Warren Services Ltd.

000733819

2009-06-30

Mojumder Auto Inc.

002046808

2009-06-30

Nex Flow International Inc.

001553074

2009-06-30

Novae Inc.

002091657

2009-06-30

Project Ornithopter Incorporated

001117594

2009-06-30

Roboraptor Inc.

001117593

2009-06-30

Ter-End Tool & Die Ltd.

000854054

2009-06-30

1215199 Ontario Inc.

001215199

2009-06-30

1273375 Ontario Ltd.

001273375

2009-06-30

1481585 Ontario Ltd.

001481585

2009-06-30

1716264 Ontario Inc.

001716264

2009-06-30

1720306 Ontario Inc.

001720306

2009-06-30

2094264 Ontario Inc.

002094264

2009-07-02

Asr Inc.

001587081

2009-07-02

Devcor Construction & Engineering Ltd.

000494315

2009-07-02

Ftoc Canada Inc.

001308488

2009-07-02

That’s It Productions Inc.

001375727

2009-07-02

The Payless Store Inc.

001628890

2009-07-02

Tyvan Holdings Ltd.

001240406

2009-07-02

1251925 Ontario Inc.

001251925

2009-07-02

1406797 Ontario Inc.

001406797


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(142-G390)

Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites sociétés.  La date d'entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2009-06-17

Lutech Mechanical Consulting Ltd.

783678

2009-06-17

Mccarthy Hospitality Inc.

1597760

2009-06-17

Symtech Canada Ltd.

729248

2009-06-17

Symtech Distribution Inc.

1608838

2009-06-25

1706294 Ontario Inc.

1706294

2009-06-26

Cotayca Inc.

1011249

2009-06-26

536998 Ontario Ltd.

536998

2009-06-26

1695688 Ontario Inc.

1695688

2009-07-03

Dana Davenport Inc.

1636495

2009-07-03

Factory Outlet Tire Inc.

1683184

2009-07-03

Seeline Group Ltd.

1644090

2009-07-03

Wismer Estates Inc.

2125520

2009-07-08

Pendleton Translations Inc.

2033967

2009-07-08

Trensept Automation Inc.

1238884


Katherine M. Murray
Directrice
(142-G391)

Annulation de certificat de constitution en personne morale (Loi sur les sociétés par actions)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats présentés ci-dessous ont été annulés et les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des sociétés concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2009-01-16

Richmond Wellness Center Inc.

1789142

2009-01-16

1784496 Ontario Limited

1784496

2009-01-16

1784694 Ontario Ltd.

1784694

2009-01-16

1784695 Ontario Ltd.

1784695

2009-01-16

1789282 Ontario Limited

1789282

2009-07-06

1051042 Ontario Limited

1051042


Katherine M. Murray
Directrice
(142-G392)

Annulation à juste titre (Loi sur les sociétés par actions)

Avis Est Donné Par La Présente que, par des ordres donnés en vertu de l’article 240 de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats indiqués ci-dessous ont été annulés à juste titre et, dans le cas des certificats de constitution, les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des sociétés concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2009-07-08

Countrywide Concept Cleaning Inc.

1636515

2009-07-08

North City Holdings Ltd.

505334


Katherine M. Murray
Directrice
(142-G393)

Avis d’erreur

Cf. Gazette de l’Ontario, Vol. 142-25, datée du 20 juin 2009, page 1727

Par La Présente, nous vous informons que la liste publiée sous le titre Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales conformément au paragraphe 241 (3) de la Loi sur les sociétés par actions a été placée incorrectement.

La liste devrait figurer sous le titre suivant :

Annulation de certificat de constitution en personne morale (paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions)

Katherine M. Murray
Directrice
(142-G394)

Loi sur le marriage

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

29 juin-30 juin

Date

Nom

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

August 5, 2009 to August 9, 2009

McDonald, Dennis

Calgary, AB

29-Jun-09

July 30, 2009 to August 3, 2009

Sabourin, Thomas

La Pêche, QC

29-Jun-09

July 22, 2009 to July 26, 2009

Gannett, Ronald George

Birmingham, AL</p>

29-Jun-09

September 3, 2009 to September 7, 2009

Vallelly, Phillip Alexander

Winkler, MB

29-Jun-09

July 30, 2009 to August 3, 2009

Emerson, Paul

Harrisonburg, VA

29-Jun-09

July 27, 2009 to July 31, 2009

Coleman, Donald Bruce

Delaware, OH

29-Jun-09

July 31, 2009 to August 4, 2009

Stuart, Roy

Wakefield, QC

29-Jun-09


Judith M. Hartman,
Registraire générale adjointe de l’état civil
(142-G395)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

2 juillet-3 juillet

Nom

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

Prevost, Muguette

Val des Monts, QC

02-Jul-09

Shoesmith, Denise

Toronto, ON

02-Jul-09

Balkwill, Laura-Lee

Kingston, ON

02-Jul-09

Cox, Sean

Prescott, ON

02-Jul-09

Long, Norman

Cavan, ON

02-Jul-09

Nagy, Robert Craig

Windsor, ON

02-Jul-09

Audigé, Steevens

Etobicoke, ON

02-Jul-09

Nguyen, Quang

Richmond Hill, ON

02-Jul-09

Martin, Ian Allan

Kingston, ON

02-Jul-09

Moskoff, Bernard

Toronto, ON

02-Jul-09

Walters, Carl Errol

Brampton, ON

02-Jul-09

Palik, Tanya

Oakville, ON

02-Jul-09

Gillian, Carolyn

London, ON

02-Jul-09

Hawkins, Erin

Windsor, ON

02-Jul-09

Yellowhead, Frank

Fort Hope, ON

02-Jul-09

Ballow, Michelle

Ottawa, ON

02-Jul-09

Curry, Brian Edward

Hamilton, ON

02-Jul-09

Simango, David

Toronto, ON

02-Jul-09

Weber, Patrick

Toronto, ON

02-Jul-09

Jones, Brooke Kaye

Caledon, ON

02-Jul-09

Driedger, David

Shakespeare, ON

02-Jul-09

Scott, Peter Ronald

New Hamburg, ON

02-Jul-09

Boulet, Dominique

Toronto, ON

02-Jul-09

Guéguen, Roger

Toronto, ON

02-Jul-09

Wegner, Jürgen

Toronto, ON

02-Jul-09


Réinscriptions

Nom

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

Mieto, Michael

Ottawa, ON

02-Jul-09


Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Date

Nom

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

July 2, 2009 to July 6, 2009

Bizzotto, Giovanni

Sun Valley, CA

30-Jun-09


Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Nom

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

Cox, Sean

Prescott, ON

02-Jul-09


Judith M. Hartman,
Registraire générale adjointe de l’état civil
(142-G396)

Loi sur le Changement de Nom

Avis est par la présente donné que les changements de noms mentionnés ci-après ont été accordés au cours de la période du 29 juin 2009 au 5 juillet 2009, en vertu de la Loi sur le changement de nom, L.R.O 1990, chap. C.7, et du Règlement 68, R.R.O 1990, s’y rapportant. La liste indique l’ancien nom suivi du nouveau nom.

Date

Ancien Nom

Nouveau Nom

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Abdullahi, Ambaro.Keyf.

Mohamed, Ismahan.Mumin..

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Abdulmajid, No'Oman.

Habib, Neuman.Omar.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Abdulmajid, Omar.

Habib, Omar.Neuman.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Agard, Karlie.Amanda.

Patrick, Karlie.Amanda.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Arce, Carlos.Ivan.

Avellaneda, Ivan.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Bai, Meng.Shi.

Bai, Kyle.Meng.Shi.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Biyong Ngo Beguel, Biyong.Ngo.Beguel.

Biyong Ngo Beguel, Irène.Coretta.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Cooper, Tyler.Anthony.

Fleetwood, Tyler.Anthony.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Costa Figueiredo de Castro, Argentina.

Costa Figueiredo, Argentina..

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Dam, Phuong.

Luong, Beth.Phuong.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Danish, Ali.

Sutani, Ali.Danish.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Dedoli Feri, Beljkez.

Dedolli Ferri, Belkez.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Desjardins, Marie.Donna.

Azur, Jazira.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Epolo, Ngunya.

Epolo-Mayela, Régine.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Farrar, Bryce.Aaron.

Simpson, Bryce.Aaron.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Favretto, Joseph.Dennis.

Favretto, Dennis.Joseph.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Feri, Aljberta.

Ferri, Alberta..

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Feri, Fljoriana.

Ferri, Floriana.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Feri, Pranvera.

Ferri, Pranvera.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Feri, Sokolj.

Ferri, Sokol.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Gagnon, Susanne.Marie.Alec.

Gagnon, Suzanne.Marie.Alexandrina.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Gong Zhi Jian, Gong.Zhi.Jian.

Kung, Chi.Kin.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Gonyea, Ryan.Michael.David.

Jordan, Ryan.Michael.David.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Grimes, Mary.Patricia.

Grimes, Jacqueline.Elizabeth.Lexi.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Hashmi, Mohammad.Nizam-.

Hashmi, Nizam.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Hollingsworth, Andrina.Wason.

Peretti, Andrina.Wason.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Hunt-Cooper, Bryanne.Yvonne.Grace.May.

Hunt, Bryanne.Yvonne.Grace.May.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Iozia, Concetta.

Iozia, Tina.Concetta.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Kanaichev, Vyacheslav.

Belof, Seva.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Kandasamy, Suntharalingam.

Kandasamy, Sunthar.Sean.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Liu, Jun.Nathan.

Liu, Nathan.Jun.Yan.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Londry, Shawna.Katherine.Prest.

Tremback, Shawna.Katherine.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Luong, Jeff.Erin.

Luong, Jeff.Aaron.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Maitland, Cherie.Victoria.

Maitland, Cheire.Victoria.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Maung, Aung.Ko.Oo.Helly.Chin.

Chin, Helly.Jin.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Miller, Carly.Raeanne.

Miller-Da Rosa, Carley.Raeanne.Alexis.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Mohamed, Abdullahi.Ahmed.

Michael, Berhane.Tekie.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Montgomery-Ratcliffe, Jocelyn.Rachel.

Watson, Jocelyn.Michelle.Pearl.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Owsley, Tristyn.Rae.Kira.

Tripp, Tristyn.Rae.Kira.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Panov, Yaron.Lucian.

Panov, Lucian.Yaron.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Parankin, Oleksandr.Oleksandrovych.

Parankin, Alexander..

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Parankina, Inna.Tarasivna.

Parankin, Inna.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Parankina, Oleksandra.Oleksandrivna.

Parankin, Alexandra.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Patel, Samitbhai.Dineshbhai.

Patel, Samit.D.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Patel, Sonia.Arvind.

Patel, Sonia.S.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Patel, Upenddrakumar.Manubhai.

Patel, Upendrakumar.Manubhai.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Ramos, Jonathan.Ryan.

Ramos, Jonathan.Ryan.Fernando.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Riggio, Novah.Cassandra.

Cassaday, Novah.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Robertson, Terri.Lynn.

Robertson, Crickett.Lynn.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Sharma, Desmond.Paul.

Abdul Jabbar, Rasheed.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Sim, Bradley.Richard.William.James.

Roach, Bradley.Richard.William.James.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Singh, Paramjit.

Pawan, Paramjit.Singh.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Szuky, Dylan.James.

Simpson, Dylan.James.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Taleb, Maan.Nazem.

Nader, Sultan.N.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Tang, Joyce.Wai.Yi.

Crysler, Joyce.Tang..

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Tate, Mary.Judith..

Tate, Jude.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Trochymchuk, John-Wilfred.

Trochimchuk, Wilfred.John.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Tshikala, Nkongolo.Kabangu.

Nkongolo, Alain.Kabangu.Tshikala.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

White, Wayne.Ross..

Hendsbee, Wayne.Ross.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Williamson, Toni.

Davies, Antoinette.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Xu, Hui.

Midwinter, Lily.Hui.Xu.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Xue, Xu.Hao.

Midwinter, Max.Xuhao.Xue.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Yang, Jin.Joo.

Jhung, Jinny.Jin.Joo.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Yeboah, Felicia.Boadi.

Boadi, Benita.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Young, Trudy-Ann.Alicia.

Anitafrika, D'Bi.Young.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Yu, Jia.

Yu, Jessica.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Zheng, Hao.

Zheng, Tony.

29 juin 2009 au 5 juillet 2009

Zheng, Jian.Yu.

Zheng, Eric.


Judith M. Hartman,
Registraire générale adjointe de l’état civil
(142-G397)